-
FOREPOD LIMITED - Tickton Hall, Tickton, Beverley, East Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07102332
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Tickton Hall
- Tickton
- Beverley
- East Yorkshire
- HU17 9RX Tickton Hall, Tickton, Beverley, East Yorkshire, HU17 9RX UK
Management
- Geschäftsführung
- FOREMAN, Andrew Patrick
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.12.2009
- Alter der Firma 2009-12-11 14 Jahre
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew Patrick Foreman
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Voluntary Arrangement
- Ehemalige Namen
- ECO MODULAR MANUFACTURING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-05
- Letzte Einreichung: 2023-04-21
-
FOREPOD LIMITED Firmenbeschreibung
- FOREPOD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07102332. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.12.2009 registriert. FOREPOD LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ECO MODULAR MANUFACTURING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Tickton Hall erreicht werden.
Jetzt sichern FOREPOD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Forepod Limited - Tickton Hall, Tickton, Beverley, East Yorkshire, Grossbritannien
- 2009-12-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FOREPOD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-21) - CS01
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2023-06-19) - CVA1
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-11) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2022-11-29) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-11-30) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-06) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-12-07) - DISS40
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-22) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-03-01) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-05-06) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-21) - CS01
-
resolution (2021-02-11) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-20) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-02) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-21) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-11) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-06-10) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-09) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-05-30) - GAZ1
-
gazette-notice-compulsory (2017-03-14) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-03-22) - DISS40
keyboard_arrow_right 2016
-
second-filing-of-form-with-form-type (2016-04-15) - RP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-06) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-09) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-09-02) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-12) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-09-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-10-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-11) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-09-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-08-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-secretary-company-with-name (2010-10-26) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-09-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-12-11) - NEWINC