-
GRESLEY DEVELOPMENTS LIMITED - 26 Little Burton West, Burton On Trent, Staffordshire, DE14 1PP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07101739
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 26 Little Burton West
- Burton On Trent
- Staffordshire
- DE14 1PP
- England 26 Little Burton West, Burton On Trent, Staffordshire, DE14 1PP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ROBINSON, Peter Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.12.2009
- Alter der Firma 2009-12-11 14 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Derek Simon
- -
- Pete Robinson (Gresley) Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-08-28
- Letzte Einreichung: 2019-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-09
- Letzte Einreichung: 2021-03-26
-
GRESLEY DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- GRESLEY DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07101739. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.12.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 26 Little Burton West erreicht werden.
Jetzt sichern GRESLEY DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gresley Developments Limited - 26 Little Burton West, Burton On Trent, Staffordshire, DE14 1PP, Grossbritannien
- 2009-12-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GRESLEY DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-05-28) - AA01
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-13) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-03) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-08-04) - DISS40
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-07) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-06) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-06) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-06) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-06) - PSC07
-
resolution (2020-01-27) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-02-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-05) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-11-06) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2020-11-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-02-23) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-19) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-19) - AD01
-
resolution (2013-04-25) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-28) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-10-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-06) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-26) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-29) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-01-06) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-12-15) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-12-15) - AD01
-
resolution (2010-05-18) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-12-11) - NEWINC