-
NIGHTINGALE HOSPICE TRADING LIMITED - 187a Baker Street Baker Street, Enfield, EN1 3JT, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07098712
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 187a Baker Street Baker Street
- Enfield
- EN1 3JT
- England 187a Baker Street Baker Street, Enfield, EN1 3JT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BONE, Andrew Wells
- SETH, Samantha Charlotte
- HENRY, Felicity Mary-Clare
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.12.2009
- Alter der Firma 2009-12-08 14 Jahre
- SIC/NACE
- 47799
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- The Nightingale Cancer Support Centre
- The Nightingale Cancer Support Centre
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-12-12
- Letzte Einreichung: 2021-11-28
-
NIGHTINGALE HOSPICE TRADING LIMITED Firmenbeschreibung
- NIGHTINGALE HOSPICE TRADING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07098712. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.12.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47799" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 187A Baker Street Baker Street erreicht werden.
Jetzt sichern NIGHTINGALE HOSPICE TRADING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nightingale Hospice Trading Limited - 187a Baker Street Baker Street, Enfield, EN1 3JT, England, Grossbritannien
- 2009-12-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NIGHTINGALE HOSPICE TRADING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-12-06) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-08-17) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-20) - AA
-
withdrawal-of-the-directors-residential-address-register-information-from-the-public-register (2018-03-02) - EW02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-02) - AD01
-
elect-to-keep-the-directors-residential-address-register-information-on-the-public-register (2018-03-02) - EH02
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-09) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-10) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-09) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2013-06-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-07-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-12-11) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-09) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2010-06-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-06-11) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-04-19) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-26) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-25) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-12-08) - NEWINC