-
ICCL LTD - Peckforton Castle Stone House Lane, Peckforton, Tarporley, CW6 9TN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07096889
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Peckforton Castle Stone House Lane
- Peckforton
- Tarporley
- CW6 9TN
- England Peckforton Castle Stone House Lane, Peckforton, Tarporley, CW6 9TN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- NAYLOR, Christopher James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.12.2009
- Alter der Firma 2009-12-07 14 Jahre
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Boutique Hotel Group Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ICCL HOLDINGS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-07-31
- Letzte Einreichung: 2020-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-12-21
- Letzte Einreichung: 2021-12-07
-
ICCL LTD Firmenbeschreibung
- ICCL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07096889. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.12.2009 registriert. ICCL LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ICCL HOLDINGS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Peckforton Castle Stone House Lane erreicht werden.
Jetzt sichern ICCL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Iccl Ltd - Peckforton Castle Stone House Lane, Peckforton, Tarporley, CW6 9TN, Grossbritannien
- 2009-12-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ICCL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-13) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-05-07) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-01-04) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-01-08) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-01-09) - SH08
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-10) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-15) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-17) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-08-17) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-17) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-17) - PSC07
-
resolution (2018-08-20) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-24) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-11-05) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-17) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-17) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-21) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-09-28) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-03-16) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-11) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2016-03-15) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-09-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-09) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-07-09) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-06-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-27) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-09-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-group (2011-09-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-04-23) - SH01
-
resolution (2010-04-23) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-04-20) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-17) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2009-12-15) - TM01
-
incorporation-company (2009-12-07) - NEWINC