-
YORK HOGROAST LIMITED - The Hart Shaw Building Europa Link, Sheffield Business Park, Sheffield, S9 1XU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07093619
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Hart Shaw Building Europa Link
- Sheffield Business Park
- Sheffield
- S9 1XU The Hart Shaw Building Europa Link, Sheffield Business Park, Sheffield, S9 1XU UK
Management
- Geschäftsführung
- CHADWICK, Stephen
- PLANT, Bryan Ian
- Prokuristen
- FOX, Roy
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.12.2009
- Gelöscht am:
- 2020-08-26
- SIC/NACE
- 56103
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- York Roast Co Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-10-31
- Letzte Einreichung: 2019-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-02
-
YORK HOGROAST LIMITED Firmenbeschreibung
- YORK HOGROAST LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07093619. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 02.12.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56103" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 02.12.2012.Die Firma kann schriftlich über The Hart Shaw Building Europa Link erreicht werden.
Jetzt sichern YORK HOGROAST LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: York Hogroast Limited - The Hart Shaw Building Europa Link, Sheffield Business Park, Sheffield, S9 1XU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu YORK HOGROAST LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-08-26) - GAZ2
-
liquidation-disclaimer-notice (2020-01-27) - NDISC
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-05-26) - LIQ14
-
liquidation-disclaimer-notice (2020-03-09) - NDISC
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-14) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-10-12) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-10-12) - 600
-
resolution (2019-10-12) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-08-14) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-15) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-12) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-20) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-14) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-12-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-25) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-02-18) - AA01
-
gazette-notice-compulsary (2011-04-26) - GAZ1
-
termination-secretary-company-with-name (2011-05-17) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2011-05-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-17) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-05-18) - AP03
-
capital-allotment-shares (2011-05-23) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-18) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-05-21) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-04) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-06) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-12-02) - NEWINC