-
ARMSTRONG & HAIRE LIMITED - 14 David Mews, London, W1U 6EQ, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07085369
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 14 David Mews
- London
- W1U 6EQ
- England 14 David Mews, London, W1U 6EQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SCHONBERG, Jonathan David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.11.2009
- Alter der Firma 2009-11-24 14 Jahre
- SIC/NACE
- 86230
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- April Holdings Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-01-31
- Letzte Einreichung: 2022-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-08
- Letzte Einreichung: 2022-11-24
-
ARMSTRONG & HAIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- ARMSTRONG & HAIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07085369. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.11.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86230" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.11.2012.Die Firma kann schriftlich über 14 David Mews erreicht werden.
Jetzt sichern ARMSTRONG & HAIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Armstrong & Haire Limited - 14 David Mews, London, W1U 6EQ, England, Grossbritannien
- 2009-11-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ARMSTRONG & HAIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-02-15) - MR04
-
resolution (2023-02-08) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2023-02-08) - MA
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2023-02-14) - MR05
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-02-14) - MR01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-16) - AA
-
memorandum-articles (2022-03-01) - MA
-
resolution (2022-01-19) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-11) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-24) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-25) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-08-16) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-07) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-21) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-07-06) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-05) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-05) - PSC02
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-07-05) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-03-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-22) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-17) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-01-28) - CH03
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-21) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-08-12) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-11-24) - NEWINC