-
M & S MOTOR VEHICLE SERVICES LIMITED - Unit 4c Hampton Lovett Industrial Estate, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07068930
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 4c Hampton Lovett Industrial Estate
- Droitwich
- Worcestershire
- WR9 0QG Unit 4c Hampton Lovett Industrial Estate, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QG UK
Management
- Geschäftsführung
- HAWKESWOOD, Shaun Lee
- STREETER, Martin Wesley
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.11.2009
- Alter der Firma 2009-11-06 14 Jahre
- SIC/NACE
- 45200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-18
- Letzte Einreichung: 2020-11-04
-
M & S MOTOR VEHICLE SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- M & S MOTOR VEHICLE SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07068930. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.11.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 4C Hampton Lovett Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern M & S MOTOR VEHICLE SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: M & S Motor Vehicle Services Limited - Unit 4c Hampton Lovett Industrial Estate, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QG, Grossbritannien
- 2009-11-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu M & S MOTOR VEHICLE SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-06) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-07) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-13) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-11) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-07-15) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-01-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-25) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-01-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
capital-allotment-shares (2009-12-16) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name (2009-12-15) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2009-12-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-15) - AP01
-
incorporation-company (2009-11-06) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-12-15) - AD01