-
BDP PATTERN LIMITED - 11 Ducie Street, Piccadilly Basin, Manchester, M60 3JA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07059878
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11 Ducie Street
- Piccadilly Basin
- Manchester
- M60 3JA
- England
- 85 11 Ducie Street, Piccadilly Basin, Manchester, M60 3JA, England, 85 UK
Management
- Geschäftsführung
- PATEL, Dipesh Jagdish
- ELLIOIT, Gavin James
- ELLIOTT, Gavin James
- FAIRHAM, Nicholas Stuart
- WELLS, Heather Olwyn
- WELLS, Heather Olwyn
- Prokuristen
- WELLS, Heather Olwyn
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.10.2009
- Alter der Firma 2009-10-28 14 Jahre
- SIC/NACE
- 71111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dipesh Jagdish Patel
- -
- Building Design Partnership Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800R84G3T39ZYMV64
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-26
- Letzte Einreichung: 2021-10-12
-
BDP PATTERN LIMITED Firmenbeschreibung
- BDP PATTERN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07059878. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.10.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71111" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 11 Ducie Street erreicht werden.
Jetzt sichern BDP PATTERN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bdp Pattern Limited - 11 Ducie Street, Piccadilly Basin, Manchester, M60 3JA, Grossbritannien
- 2009-10-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BDP PATTERN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-12) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-17) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-15) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-07-06) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-06) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-07-06) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-06) - CH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-07-06) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-07-06) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-29) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-05) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-01-04) - AP03
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-07-17) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-10-12) - PSC07
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-03-16) - RP04CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-17) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2019-01-15) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-01-19) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-27) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-16) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-12) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-24) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-03) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-05-21) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-10) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-10) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-02-18) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-02-17) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-10-28) - NEWINC