-
FUTUREPATH CHILDCARE LTD - Tuscany House, White Hart Lane, Basingstoke, RG21 4AF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07052955
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Tuscany House
- White Hart Lane
- Basingstoke
- RG21 4AF
- England Tuscany House, White Hart Lane, Basingstoke, RG21 4AF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LAWSON, Colin James
- MOORE, Adrian Richard
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.10.2009
- Alter der Firma 2009-10-22 14 Jahre
- SIC/NACE
- 85100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Jacky Barnett
- -
- Miss Peter David Barnett
- -
- Grandir Uk Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-10-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-06
- Letzte Einreichung: 2019-11-22
-
FUTUREPATH CHILDCARE LTD Firmenbeschreibung
- FUTUREPATH CHILDCARE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07052955. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.10.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.10.2014.Die Firma kann schriftlich über Tuscany House erreicht werden.
Jetzt sichern FUTUREPATH CHILDCARE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Futurepath Childcare Ltd - Tuscany House, White Hart Lane, Basingstoke, RG21 4AF, Grossbritannien
- 2009-10-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FUTUREPATH CHILDCARE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-12) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-20) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-03-11) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-12) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-11-22) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-04) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-06-07) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-04) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-03) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-10) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-07) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-29) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-08-09) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-11-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-16) - AR01
-
legacy (2011-05-21) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-02-22) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-02-22) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-08-02) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-10-22) - NEWINC