-
LUST PROMOTIONS LTD - Penny Lane Business Centre, 374 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07048893
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Penny Lane Business Centre
- 374 Smithdown Road
- Liverpool
- Merseyside
- L15 5AN Penny Lane Business Centre, 374 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside, L15 5AN UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, Simon Neale
- Prokuristen
- DAVIES, Simon Neale
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.10.2009
- Alter der Firma 2009-10-19 14 Jahre
- SIC/NACE
- 47110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Neale Davies
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-30
- Letzte Einreichung: 2020-10-16
-
LUST PROMOTIONS LTD Firmenbeschreibung
- LUST PROMOTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07048893. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.10.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Penny Lane Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern LUST PROMOTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lust Promotions Ltd - Penny Lane Business Centre, 374 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside, Grossbritannien
- 2009-10-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LUST PROMOTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-21) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-27) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-12) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-12) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2016-06-17) - RP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-10-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-01) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-05) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-02) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-12) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-12-11) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-secretary-company-with-name (2011-01-07) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-10) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-25) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-14) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-25) - AD01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-11-28) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-24) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-09-24) - AP03
-
capital-allotment-shares (2010-05-27) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-05-27) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-05-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
termination-director-company-with-name (2009-10-22) - TM01
-
incorporation-company (2009-10-19) - NEWINC