-
TYNE GANGWAY (STRUCTURES) LIMITED - Benbecula Office, Wincomblee Road, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07038655
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Benbecula Office
- Wincomblee Road
- Newcastle Upon Tyne
- Tyne And Wear
- NE6 3QS
- England Benbecula Office, Wincomblee Road, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, NE6 3QS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MACDONALD, Alasdair
- REECE, John Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.10.2009
- Alter der Firma 2009-10-13 14 Jahre
- SIC/NACE
- 25990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Lift-Rite Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SPEED 9999 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-24
- Letzte Einreichung: 2019-10-13
-
TYNE GANGWAY (STRUCTURES) LIMITED Firmenbeschreibung
- TYNE GANGWAY (STRUCTURES) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07038655. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.10.2009 registriert. TYNE GANGWAY (STRUCTURES) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SPEED 9999 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Benbecula Office erreicht werden.
Jetzt sichern TYNE GANGWAY (STRUCTURES) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tyne Gangway (Structures) Limited - Benbecula Office, Wincomblee Road, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, Grossbritannien
- 2009-10-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TYNE GANGWAY (STRUCTURES) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-15) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-02-13) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-04) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-01-15) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-03) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-03) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-07-19) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-13) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-13) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-11) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-09-02) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-15) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-26) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-28) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-17) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-25) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-02-20) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2013-02-19) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-25) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-08) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-18) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-16) - CH01
-
certificate-change-of-name-company (2010-11-16) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2010-11-05) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-10-26) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-10-05) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-10-13) - NEWINC