-
MASTERPAY SERVICES LIMITED - C/O Kingsland Business Recovery, 14 Derby Road, Stapleford, NG9 7AA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07022058
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Kingsland Business Recovery
- 14 Derby Road
- Stapleford
- NG9 7AA C/O Kingsland Business Recovery, 14 Derby Road, Stapleford, NG9 7AA UK
Management
- Geschäftsführung
- SYKES, Robert
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.09.2009
- Gelöscht am:
- 2020-12-15
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Masterpay Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-03-31
- Letzte Einreichung: 2015-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-10-01
- Letzte Einreichung: 2016-09-17
-
MASTERPAY SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- MASTERPAY SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07022058. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 17.09.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Kingsland Business Recovery erreicht werden.
Jetzt sichern MASTERPAY SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Masterpay Services Limited - C/O Kingsland Business Recovery, 14 Derby Road, Stapleford, NG9 7AA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MASTERPAY SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-12-15) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-09-15) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-06-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-07-30) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-06-26) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-notice-compulsory (2017-05-30) - GAZ1
-
liquidation-disclaimer-notice (2017-05-29) - NDISC
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2017-05-28) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-05-28) - 600
-
resolution (2017-05-28) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-03) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-30) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-18) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-30) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-30) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-01-22) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-12-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-30) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-28) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-19) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-25) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-20) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2011-05-26) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-01-06) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2011-01-06) - TM02
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-17) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-03-03) - AA01
-
legacy (2010-02-11) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-23) - CH01
-
incorporation-company (2009-09-17) - NEWINC
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2009-11-23) - CH03