-
222 SPORTS LIMITED - 6 Charlotte Street, Bath, BA1 2NE, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07019129
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6 Charlotte Street
- Bath
- BA1 2NE
- England 6 Charlotte Street, Bath, BA1 2NE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BADDELEY, David William
- MAXWELL, Philip
- SLOYAN, Kieran
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.09.2009
- Alter der Firma 2009-09-15 14 Jahre
- SIC/NACE
- 27900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kieran Sloyan
- Mr Philip Maxwell
- Mr David William Baddeley
- Mr Kieran Sloyan
- Mr Philip Maxwell
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-29
- Letzte Einreichung: 2022-09-15
-
222 SPORTS LIMITED Firmenbeschreibung
- 222 SPORTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07019129. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.09.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "27900" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 6 Charlotte Street erreicht werden.
Jetzt sichern 222 SPORTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 222 Sports Limited - 6 Charlotte Street, Bath, BA1 2NE, England, Grossbritannien
- 2009-09-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 222 SPORTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-09-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-10) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-13) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-10) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-08-10) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-08) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-17) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-31) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-01) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-05) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-10) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-15) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-15) - PSC04
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-09-28) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-06) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-19) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-18) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-04-11) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-01) - AA
-
capital-allotment-shares (2012-02-24) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-10-13) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-09) - AA
-
appoint-corporate-director-company-with-name (2011-02-16) - AP02
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-29) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-29) - AR01
-
capital-allotment-shares (2010-12-20) - SH01
-
legacy (2010-10-29) - MG01
-
capital-allotment-shares (2010-11-25) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-09-15) - NEWINC