-
CITYBLOCK (LEICESTER 2) LIMITED - 21 Castle Hill, Lancaster, LA1 1YN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06999434
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 21 Castle Hill
- Lancaster
- LA1 1YN 21 Castle Hill, Lancaster, LA1 1YN UK
Management
- Geschäftsführung
- BARGH, Alison Jane
- BARGH, John Trevor
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.08.2009
- Alter der Firma 2009-08-24 14 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Cityblock Holdings Limited
- Cityblock Holdings (Leicester 2) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-26
- Letzte Einreichung: 2020-06-12
-
CITYBLOCK (LEICESTER 2) LIMITED Firmenbeschreibung
- CITYBLOCK (LEICESTER 2) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06999434. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.08.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 21 Castle Hill erreicht werden.
Jetzt sichern CITYBLOCK (LEICESTER 2) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cityblock (Leicester 2) Limited - 21 Castle Hill, Lancaster, LA1 1YN, Grossbritannien
- 2009-08-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CITYBLOCK (LEICESTER 2) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-04-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-26) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-12) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-07-27) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-13) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-13) - PSC02
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-17) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-06-03) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-06-10) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-06) - AR01
-
auditors-resignation-company (2015-07-31) - AUD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-06-08) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-23) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-10-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-08) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-08) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-12-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-12-21) - AA
-
resolution (2012-10-08) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-26) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-08-25) - AA
-
auditors-resignation-company (2011-08-24) - AUD
-
legacy (2011-06-15) - MG02
-
legacy (2011-05-28) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-07-08) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-24) - AA
-
legacy (2010-08-26) - MG01
-
resolution (2010-09-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2010-09-01) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-22) - AR01
-
legacy (2010-10-15) - MG01
-
legacy (2010-10-23) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-24) - 395
-
resolution (2009-09-29) - RESOLUTIONS
-
legacy (2009-09-29) - 288a
-
legacy (2009-09-29) - 128(4)
-
capital-allotment-shares (2009-10-09) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-10-27) - AP01
-
legacy (2009-11-18) - MG01
-
incorporation-company (2009-08-24) - NEWINC