-
WORKFLOW MANAGED NETWORKS LIMITED - PO BOX 501 The Nexus Building, Broadway, Letchworth Garden City, Herts, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06990719
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- PO BOX 501 The Nexus Building
- Broadway
- Letchworth Garden City
- Herts
- SG6 9BL PO BOX 501 The Nexus Building, Broadway, Letchworth Garden City, Herts, SG6 9BL UK
Management
- Geschäftsführung
- BAKER, Gary Edward
- JEST, Robin Malcolm
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.08.2009
- Gelöscht am:
- 2020-09-22
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Graham John Mcmullen
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- ADMIRAL SOLUTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-02-24
- Letzte Einreichung: 2018-02-10
-
WORKFLOW MANAGED NETWORKS LIMITED Firmenbeschreibung
- WORKFLOW MANAGED NETWORKS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06990719. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 14.08.2009 registriert. WORKFLOW MANAGED NETWORKS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ADMIRAL SOLUTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.08.2012.Die Firma kann schriftlich über Po Box 501 The Nexus Building erreicht werden.
Jetzt sichern WORKFLOW MANAGED NETWORKS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Workflow Managed Networks Limited - PO BOX 501 The Nexus Building, Broadway, Letchworth Garden City, Herts, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WORKFLOW MANAGED NETWORKS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-11-07) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-15) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-14) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-06) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-06) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-10-24) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-notice-compulsory (2017-01-03) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-27) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-01-28) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-04-22) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2015-03-26) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-03) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-10) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-01-30) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-10-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-08) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-01-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-15) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-28) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2012-08-16) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-24) - AP01
-
legacy (2012-07-18) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-02) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-02-02) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2011-02-02) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2011-02-02) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-14) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2011-07-29) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-09-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-26) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2009-12-17) - AA01
-
incorporation-company (2009-08-14) - NEWINC