-
BUDGEPRINT LIMITED - Ground Floor, 19 New Road, Brighton, BN1 1UF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06983121
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ground Floor
- 19 New Road
- Brighton
- BN1 1UF
- United Kingdom Ground Floor, 19 New Road, Brighton, BN1 1UF, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ENTECOTT, Edward Robert
- ENTECOTT, Richard Charles
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.08.2009
- Gelöscht am:
- 2023-11-14
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Mr Richard Charles Entecott
- Document Options Ltd
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-06
- Letzte Einreichung: 2020-07-23
-
BUDGEPRINT LIMITED Firmenbeschreibung
- BUDGEPRINT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06983121. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.08.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.08.2012.Die Firma kann schriftlich über Ground Floor erreicht werden.
Jetzt sichern BUDGEPRINT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Budgeprint Limited - Ground Floor, 19 New Road, Brighton, BN1 1UF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BUDGEPRINT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-05-20) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-03) - PSC05
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-03) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-12-09) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-24) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-07-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-07) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-06) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-16) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-03) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-17) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-26) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-02) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-04) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-04) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-08) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-27) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-04-03) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-12) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-12) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-27) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-09) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-14) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-11) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-11) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-15) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-08-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-08-06) - NEWINC