-
PURE COOKSHOP LTD - 130 Walham Green Court, Moore Park Road, London, SW6 2PX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06981188
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 130 Walham Green Court
- Moore Park Road
- London
- SW6 2PX 130 Walham Green Court, Moore Park Road, London, SW6 2PX UK
Management
- Geschäftsführung
- NICOLS, Roy Daniel
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.08.2009
- Alter der Firma 2009-08-05 14 Jahre
- SIC/NACE
- 47540
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Roy Daniel Nicols
- Mrs Kerry-Anne Nicols
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-02
- Letzte Einreichung: 2023-06-18
-
PURE COOKSHOP LTD Firmenbeschreibung
- PURE COOKSHOP LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06981188. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.08.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47540" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 130 Walham Green Court erreicht werden.
Jetzt sichern PURE COOKSHOP LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pure Cookshop Ltd - 130 Walham Green Court, Moore Park Road, London, SW6 2PX, Grossbritannien
- 2009-08-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PURE COOKSHOP LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-09-05) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-22) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-09-23) - DISS40
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-08) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-06-19) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2020-12-31) - AA01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-11-25) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2020-11-24) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-20) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-11-20) - CH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-20) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-05-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-10-22) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-12-24) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-21) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-22) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-22) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-03-22) - TM02
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-05-12) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-09) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-08) - AA
-
termination-director-company-with-name (2014-03-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-03) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-16) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-25) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-08-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-01) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-10-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-08-05) - NEWINC