-
BONDCARE 7 LIMITED - 1st Floor Cloister House Riverside, New Bailey Street, Manchester, M3 5FS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06971580
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1st Floor Cloister House Riverside
- New Bailey Street
- Manchester
- M3 5FS
- England 1st Floor Cloister House Riverside, New Bailey Street, Manchester, M3 5FS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LEVISON, Leib
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.07.2009
- Alter der Firma 2009-07-24 14 Jahre
- SIC/NACE
- 87300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Leib Levison
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Mrs Yael Levison
- Mr Leib Leib Levison
- Mrs Yael Levison
- -
- Mr Leib Levison
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SHAYLOR DEVELOPMENTS (HALESOWEN) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-27
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-07
- Letzte Einreichung: 2019-07-24
-
BONDCARE 7 LIMITED Firmenbeschreibung
- BONDCARE 7 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06971580. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.07.2009 registriert. BONDCARE 7 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SHAYLOR DEVELOPMENTS (HALESOWEN) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87300" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 1St Floor Cloister House Riverside erreicht werden.
Jetzt sichern BONDCARE 7 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bondcare 7 Limited - 1st Floor Cloister House Riverside, New Bailey Street, Manchester, M3 5FS, Grossbritannien
- 2009-07-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BONDCARE 7 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-04-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-26) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-07) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-03) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-03) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-06) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-06) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-07) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-07) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-08) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-04) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-24) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-04-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-18) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-25) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-27) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-09) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-04-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-24) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-04-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-19) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-04-15) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-25) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-02-19) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-02-19) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-02-18) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-02-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-02-18) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2010-01-04) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2010-01-04) - CONNOT
-
legacy (2010-01-04) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-07-24) - NEWINC