-
JUNIFER SYSTEMS LIMITED - 203 Eversholt Street, London, NW1 1BU, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06966818
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 203 Eversholt Street
- London
- NW1 1BU
- England 203 Eversholt Street, London, NW1 1BU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- PRIGGEN, John Edward Frederick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.07.2009
- Gelöscht am:
- 2019-12-03
- SIC/NACE
- 62020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Gentrack Holdings (Uk) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-08-03
- Letzte Einreichung: 2021-07-20
-
JUNIFER SYSTEMS LIMITED Firmenbeschreibung
- JUNIFER SYSTEMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06966818. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.07.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62020" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 203 Eversholt Street erreicht werden.
Jetzt sichern JUNIFER SYSTEMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Junifer Systems Limited - 203 Eversholt Street, London, NW1 1BU, England, Grossbritannien
- 2009-07-20
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JUNIFER SYSTEMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-07-10) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
memorandum-articles (2022-01-05) - MA
-
resolution (2022-01-05) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-03-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-10-11) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-04-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-04-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-17) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-10-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-10-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-06-08) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
restoration-order-of-court (2020-08-10) - AC92
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-09-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-10) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-dissolved-voluntary (2019-12-03) - GAZ2(A)
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-07-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-17) - TM01
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2019-05-14) - SOAS(A)
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-10) - MR04
-
gazette-notice-voluntary (2019-03-12) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2019-03-01) - DS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-20) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-20) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-07) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-07) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-01) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-04-07) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-11-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-29) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-08-29) - CH01
-
resolution (2014-07-04) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-12) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-12) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-12) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-30) - CH01
-
legacy (2010-02-22) - 88(2)
-
resolution (2010-02-18) - RESOLUTIONS
-
legacy (2010-02-17) - 88(2)
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-07-20) - NEWINC