-
HANOVER SEARCH GROUP LTD - 1 King Street, London, EC2V 8AU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06954517
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 King Street
- London
- EC2V 8AU 1 King Street, London, EC2V 8AU UK
Management
- Geschäftsführung
- EMMETT, James David
- GROARKE, Paul Michael
- KORTACH, Mehmed
- PHIPPS, Stephen Robin
- RIDD, James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.07.2009
- Alter der Firma 2009-07-07 14 Jahre
- SIC/NACE
- 78109
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr James David Emmett
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SAAM HOLDINGS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-07-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-21
- Letzte Einreichung: 2021-07-07
-
HANOVER SEARCH GROUP LTD Firmenbeschreibung
- HANOVER SEARCH GROUP LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06954517. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.07.2009 registriert. HANOVER SEARCH GROUP LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SAAM HOLDINGS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78109" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.07.2013.Die Firma kann schriftlich über 1 King Street erreicht werden.
Jetzt sichern HANOVER SEARCH GROUP LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hanover Search Group Ltd - 1 King Street, London, EC2V 8AU, Grossbritannien
- 2009-07-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HANOVER SEARCH GROUP LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-16) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-07-16) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-07-25) - MR04
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-17) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-20) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-12-21) - DISS40
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-21) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-19) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-04-30) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-09-12) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-12) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-04-30) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-06) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-26) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-02) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-01) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-30) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-05-24) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-10) - AR01
-
resolution (2012-02-17) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2012-01-19) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-secretary-company-with-name (2011-02-10) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-15) - AR01
-
change-of-name-notice (2011-12-13) - CONNOT
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-02-10) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-22) - AA
-
resolution (2011-12-13) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-21) - 88(2)
-
legacy (2009-07-10) - 288b
-
certificate-change-of-name-company (2009-08-27) - CERTNM
-
legacy (2009-07-22) - 225
-
legacy (2009-07-22) - 288a
-
incorporation-company (2009-07-07) - NEWINC