-
ARMSTRONG STORAGE & PACKAGING LTD - 184 Abbotswood Road, Brockworth, Gloucester, GL3 4PF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06942872
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 184 Abbotswood Road
- Brockworth
- Gloucester
- GL3 4PF 184 Abbotswood Road, Brockworth, Gloucester, GL3 4PF UK
Management
- Geschäftsführung
- THOMAS, Martyn
- TWINNING, Joanne
- Prokuristen
- TWINNING, Joanne
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.06.2009
- Alter der Firma 2009-06-24 14 Jahre
- SIC/NACE
- 52103
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Joanne Twinning
- Mr Martyn Thomas
- Mr Martyn Thomas
- Mrs Joanne Twinning
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GENERATE PRODUCTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-03
- Letzte Einreichung: 2023-05-20
-
ARMSTRONG STORAGE & PACKAGING LTD Firmenbeschreibung
- ARMSTRONG STORAGE & PACKAGING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06942872. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.06.2009 registriert. ARMSTRONG STORAGE & PACKAGING LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GENERATE PRODUCTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52103" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 184 Abbotswood Road erreicht werden.
Jetzt sichern ARMSTRONG STORAGE & PACKAGING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Armstrong Storage & Packaging Ltd - 184 Abbotswood Road, Brockworth, Gloucester, GL3 4PF, Grossbritannien
- 2009-06-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ARMSTRONG STORAGE & PACKAGING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-06-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-03-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-03-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-06) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-11-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-17) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-31) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-31) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-20) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-03-31) - AP03
-
certificate-change-of-name-company (2015-04-01) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-31) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-12-15) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-12) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2012-10-23) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-15) - AR01
-
legacy (2011-06-10) - MG02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-24) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-08) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-08) - CH01
-
legacy (2010-06-04) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-06-24) - NEWINC