-
LOGAN GILL HYDROELECTRIC LTD - Ellergreen Estate Office, Burneside, Kendal, Cumbria, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06941343
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ellergreen Estate Office
- Burneside
- Kendal
- Cumbria
- LA9 5SD Ellergreen Estate Office, Burneside, Kendal, Cumbria, LA9 5SD UK
Management
- Geschäftsführung
- CREWDSON, Charles William Nepean
- CROPPER, Mark Alexander James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.06.2009
- Alter der Firma 2009-06-23 14 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Majc Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-07
- Letzte Einreichung: 2020-06-23
-
LOGAN GILL HYDROELECTRIC LTD Firmenbeschreibung
- LOGAN GILL HYDROELECTRIC LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06941343. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.06.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Ellergreen Estate Office erreicht werden.
Jetzt sichern LOGAN GILL HYDROELECTRIC LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Logan Gill Hydroelectric Ltd - Ellergreen Estate Office, Burneside, Kendal, Cumbria, Grossbritannien
- 2009-06-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LOGAN GILL HYDROELECTRIC LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-02-01) - TM02
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-05-11) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-11-19) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-09-04) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-06) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-06) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-06) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-23) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-15) - AA
-
change-sail-address-company-with-new-address (2017-06-22) - AD02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-05) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-05) - PSC02
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2017-06-22) - AD03
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-06) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-02-16) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-02-16) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-24) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-06-24) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-24) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-07-01) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-05) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-08) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-01-28) - MG01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-10-29) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
resolution (2009-12-16) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2009-10-12) - SH01
-
legacy (2009-08-26) - 88(2)
-
legacy (2009-08-14) - 88(2)
-
legacy (2009-07-13) - 288a
-
legacy (2009-07-11) - 288a
-
legacy (2009-07-11) - 225
-
incorporation-company (2009-06-23) - NEWINC