-
4 3 2 1 LIMITED - Unit 28,, New England House, New England Street, Brighton, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06928849
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 28,
- New England House
- New England Street
- Brighton
- East Sussex
- BN1 4GH Unit 28,, New England House, New England Street, Brighton, East Sussex, BN1 4GH UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIS, Mark
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.06.2009
- Gelöscht am:
- 2018-03-06
- SIC/NACE
- 90030
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mark Davis
- Mr Mark Davis
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2012-08-06
- Letzte Einreichung: 2016-11-06
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2010-06-09
-
4 3 2 1 LIMITED Firmenbeschreibung
- 4 3 2 1 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06928849. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 09.06.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "90030" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 06/11/2010 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.06.2010.Die Firma kann schriftlich über Unit 28 erreicht werden.
Jetzt sichern 4 3 2 1 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 4 3 2 1 Limited - Unit 28,, New England House, New England Street, Brighton, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 4 3 2 1 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2018
-
gazette-dissolved-voluntary (2018-03-06) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-05) - AA
-
gazette-notice-voluntary (2017-12-19) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2017-12-11) - DS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-11) - AA
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2016-07-12) - 1.4
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-05) - TM01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2016-08-05) - AD02
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-05) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-05) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-15) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-15) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-26) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-31) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-27) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-09-27) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-09-27) - AR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-10) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2016-07-12) - 1.3
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-09-19) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2015-07-13) - 1.3
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2014-05-14) - 1.3
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2013-06-25) - 1.3
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2012-06-26) - 1.3
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-02-09) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2011-05-12) - 1.1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-01-07) - MG01
-
legacy (2010-02-08) - MG01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-02-11) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-02-11) - AA
-
legacy (2010-03-16) - MG01
-
legacy (2010-08-17) - MG01
-
legacy (2010-08-20) - MG01
-
change-sail-address-company (2010-09-20) - AD02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-20) - AR01
-
change-sail-address-company-with-old-address (2010-09-21) - AD02
-
legacy (2010-10-11) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-11-10) - AP01
-
legacy (2009-09-29) - 395
-
legacy (2009-08-28) - 288a
-
legacy (2009-08-11) - 288b
-
incorporation-company (2009-06-09) - NEWINC