-
DLR HOLDINGS LIMITED - 93 Cumberland Street Cumberland Street, Hull, HU2 0PU, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06927416
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 93 Cumberland Street Cumberland Street
- Hull
- HU2 0PU
- England 93 Cumberland Street Cumberland Street, Hull, HU2 0PU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CUCKNEY, David Michael Eliot
- ROEBUCK, David Lee
- WORTHY, Gareth Francis
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.06.2009
- Alter der Firma 2009-06-08 14 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Lee Roebuck
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-01-31
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-22
- Letzte Einreichung: 2019-08-08
-
DLR HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- DLR HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06927416. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.06.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 93 Cumberland Street Cumberland Street erreicht werden.
Jetzt sichern DLR HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dlr Holdings Limited - 93 Cumberland Street Cumberland Street, Hull, HU2 0PU, England, Grossbritannien
- 2009-06-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DLR HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-02) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-09) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-12-28) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-28) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-12) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-02) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-08) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-31) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-08-08) - PSC08
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2016-09-15) - MR05
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-09-01) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-27) - MR01
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2015-12-04) - MR05
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-19) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-16) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-11-21) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-17) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-31) - AA
-
legacy (2013-01-19) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-02) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-13) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-13) - AR01
-
legacy (2012-12-20) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-12-21) - AD01
-
legacy (2012-12-12) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-06-15) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2009-10-29) - AA01
-
incorporation-company (2009-06-08) - NEWINC