-
GLOBAL & PROHEALTH LIMITED - Newfield Industrial Estate, Newfield Road, Oldbury, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06916456
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Newfield Industrial Estate
- Newfield Road
- Oldbury
- West Midlands
- B69 3ET
- England Newfield Industrial Estate, Newfield Road, Oldbury, West Midlands, B69 3ET, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LUCKING, Graham Stuart
- Prokuristen
- DOBSON, Erica
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.05.2009
- Gelöscht am:
- 2019-01-15
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Lorenzo Maria Micaglio
- Mr Graham Stuart Lucking
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- WELLMAN THERMAL TECHNOLOGIES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-27
-
GLOBAL & PROHEALTH LIMITED Firmenbeschreibung
- GLOBAL & PROHEALTH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06916456. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 27.05.2009 registriert. GLOBAL & PROHEALTH LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WELLMAN THERMAL TECHNOLOGIES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/12/2010 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.05.2012.Die Firma kann schriftlich über Newfield Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern GLOBAL & PROHEALTH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Global & Prohealth Limited - Newfield Industrial Estate, Newfield Road, Oldbury, West Midlands, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GLOBAL & PROHEALTH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2019
-
gazette-dissolved-voluntary (2019-01-15) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-11) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-26) - TM01
-
gazette-notice-voluntary (2018-10-16) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2018-10-09) - DS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-25) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-07-12) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-07-13) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-05-05) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-07-25) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-07-25) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-30) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-12-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-03) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2015-09-22) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-06) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-11-04) - DISS40
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-05-27) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-28) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-13) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-06-13) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-03-11) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-14) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2013-10-08) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-01-15) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-01-20) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-03-27) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-03-27) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-27) - AP01
-
auditors-resignation-company (2012-05-22) - AUD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-11-01) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-06) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-03-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
miscellaneous (2011-12-19) - MISC
-
miscellaneous (2011-12-08) - MISC
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-09-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-10-15) - MG01
-
legacy (2009-07-06) - 225
-
incorporation-company (2009-05-27) - NEWINC