-
CARE ANALYTICAL LIMITED - Recovery House Hainault Business Park, 15-17 Roebuck Road, Ilford, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06914073
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Recovery House Hainault Business Park
- 15-17 Roebuck Road
- Ilford
- Essex
- IG6 3TU Recovery House Hainault Business Park, 15-17 Roebuck Road, Ilford, Essex, IG6 3TU UK
Management
- Geschäftsführung
- CHAPMAN, Claire Donna
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.05.2009
- Gelöscht am:
- 2023-09-26
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Brett Colin Chapman
- Mrs Claire Donna Chapman
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-02-29
- Letzte Einreichung: 2018-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-05
- Letzte Einreichung: 2019-05-22
-
CARE ANALYTICAL LIMITED Firmenbeschreibung
- CARE ANALYTICAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06914073. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 22.05.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.05.2012.Die Firma kann schriftlich über Recovery House Hainault Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern CARE ANALYTICAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Care Analytical Limited - Recovery House Hainault Business Park, 15-17 Roebuck Road, Ilford, Essex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CARE ANALYTICAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2021-05-24) - AM22
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-05-24) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-05-10) - AM10
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2020-05-01) - AM07
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2020-03-27) - AM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-30) - AD01
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2020-11-03) - AM19
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-05-18) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-11-26) - AM10
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2019-11-11) - AM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-11-01) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-15) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-28) - AA
-
liquidation-in-administration-proposals (2019-12-10) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-02-15) - AA
-
capital-allotment-shares (2011-10-28) - SH01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-14) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-30) - 395
-
legacy (2009-09-21) - 288b
-
legacy (2009-07-14) - 288a
-
legacy (2009-06-12) - 287
-
legacy (2009-06-11) - 288b
-
legacy (2009-06-11) - 288a
-
incorporation-company (2009-05-22) - NEWINC
-
legacy (2009-09-21) - 288a