-
NAL ASSET MANAGEMENT LIMITED - Hangar1 Southside, Newcastle Int Airport, Woolsington, Newcastle Upon Tyne, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06904746
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hangar1 Southside
- Newcastle Int Airport
- Woolsington
- Newcastle Upon Tyne
- NE13 8BT
- United Kingdom Hangar1 Southside, Newcastle Int Airport, Woolsington, Newcastle Upon Tyne, NE13 8BT, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BULMAN, Donna
- MCLEOD, Craig Marin
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.05.2009
- Alter der Firma 2009-05-13 15 Jahre
- SIC/NACE
- 51102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Craig Marin Mcleod
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-27
- Letzte Einreichung: 2021-05-13
-
NAL ASSET MANAGEMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- NAL ASSET MANAGEMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06904746. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.05.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "51102" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.05.2012.Die Firma kann schriftlich über Hangar1 Southside erreicht werden.
Jetzt sichern NAL ASSET MANAGEMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nal Asset Management Limited - Hangar1 Southside, Newcastle Int Airport, Woolsington, Newcastle Upon Tyne, Grossbritannien
- 2009-05-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NAL ASSET MANAGEMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-24) - CS01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-09-02) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-09-02) - LIQ02
-
resolution (2021-09-02) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-29) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-18) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-03-07) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2020-03-03) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-cancellation-shares (2019-02-12) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-02-12) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-09) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-24) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-19) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-29) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-06-29) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-25) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-05-24) - TM02
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-09) - AR01
-
mortgage-charge-whole-cease-and-release-with-charge-number (2015-04-02) - MR05
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-31) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-06-10) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-06-16) - SH08
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-10) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-12) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-08) - AR01
-
legacy (2012-04-17) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-09) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-02-15) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-11-22) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-05-13) - NEWINC