-
MA COST CONSULTING LIMITED - Bell House Seebeck Place, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8FR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06901841
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bell House Seebeck Place
- Knowlhill
- Milton Keynes
- MK5 8FR Bell House Seebeck Place, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8FR UK
Management
- Geschäftsführung
- GHAZNAVI, Yusoff
- NUNN, Andrew
- WITHEAT, Giles
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.05.2009
- Alter der Firma 2009-05-11 15 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Giles Witheat
- Mr Andrew Nunn
- Mac Cc Group Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- HC1118 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-05-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-05-25
- Letzte Einreichung: 2019-05-11
-
MA COST CONSULTING LIMITED Firmenbeschreibung
- MA COST CONSULTING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06901841. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.05.2009 registriert. MA COST CONSULTING LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HC1118 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Bell House Seebeck Place erreicht werden.
Jetzt sichern MA COST CONSULTING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ma Cost Consulting Limited - Bell House Seebeck Place, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8FR, Grossbritannien
- 2009-05-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MA COST CONSULTING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-03-11) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-03-02) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-09-19) - PSC02
-
resolution (2019-09-05) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-09-05) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-30) - PSC07
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-29) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-02-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-03-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-02-28) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-12-18) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-17) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-09-14) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-07-10) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-10) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date (2012-06-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-09) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-01-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-01-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-05-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-05-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-14) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-05-13) - CH04
-
resolution (2010-05-28) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2010-05-28) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-11-11) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
certificate-change-of-name-company (2009-12-08) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2009-12-08) - CONNOT
-
incorporation-company (2009-05-11) - NEWINC