-
PULSE UMBRELLA LIMITED - Peak View, King Edward Street, Macclesfield, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06900984
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Peak View
- King Edward Street
- Macclesfield
- Cheshire
- SK10 1AQ Peak View, King Edward Street, Macclesfield, Cheshire, SK10 1AQ UK
Management
- Geschäftsführung
- HILL, Victoria Angela
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.05.2009
- Alter der Firma 2009-05-11 15 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- The Pulse Umbrella Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PROPER UMBRELLA LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-06-19
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-25
- Letzte Einreichung: 2020-05-11
-
PULSE UMBRELLA LIMITED Firmenbeschreibung
- PULSE UMBRELLA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06900984. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.05.2009 registriert. PULSE UMBRELLA LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PROPER UMBRELLA LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Peak View erreicht werden.
Jetzt sichern PULSE UMBRELLA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pulse Umbrella Limited - Peak View, King Edward Street, Macclesfield, Cheshire, Grossbritannien
- 2009-05-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PULSE UMBRELLA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-11-17) - GAZ1
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-03-19) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-04) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-04) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-06-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-22) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-18) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-07) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-13) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-04-14) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-05-09) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-05-12) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-05) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2017-10-16) - CVA4
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2017-09-10) - CVA3
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-06-09) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2016-09-19) - 1.3
-
accounts-with-accounts-type-medium (2016-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2015-09-21) - 1.3
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-medium (2014-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-12-19) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2013-09-16) - 1.3
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2012-07-17) - 1.1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-30) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-05-04) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-06) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-05-06) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2011-05-06) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-14) - AD01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2011-07-26) - RP04
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-12-08) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
memorandum-articles (2009-09-15) - MEM/ARTS
-
certificate-change-of-name-company (2009-09-10) - CERTNM
-
incorporation-company (2009-05-11) - NEWINC