-
KELPACK HIRE LIMITED - 2 Rough Hey Road, Grimsargh, Preston, PR2 5AR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06893809
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Rough Hey Road
- Grimsargh
- Preston
- PR2 5AR 2 Rough Hey Road, Grimsargh, Preston, PR2 5AR UK
Management
- Geschäftsführung
- BRASH, David James
- BRASH, James Robert
- CECE, Michael
- HAMER, David
- BRASK, Dj
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.05.2009
- Alter der Firma 2009-05-01 14 Jahre
- SIC/NACE
- 77390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Brask And Cece Holdings Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- KELWICK 100 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-10-31
- Letzte Einreichung: 2022-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-15
- Letzte Einreichung: 2023-05-01
-
KELPACK HIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- KELPACK HIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06893809. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.05.2009 registriert. KELPACK HIRE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen KELWICK 100 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77390" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/12/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2 Rough Hey Road erreicht werden.
Jetzt sichern KELPACK HIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kelpack Hire Limited - 2 Rough Hey Road, Grimsargh, Preston, PR2 5AR, Grossbritannien
- 2009-05-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KELPACK HIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-10-27) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-10-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-01-05) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-10-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-11-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-11-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-11-13) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-01-16) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-03-18) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-03-18) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-24) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-18) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-25) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-05) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-12-08) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-29) - AP01
-
auditors-resignation-company (2013-10-03) - AUD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-29) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-05-29) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-08-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-17) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-05-27) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-06) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2010-05-27) - TM02
-
legacy (2010-11-12) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-05-01) - NEWINC
-
legacy (2009-05-05) - 288b
-
legacy (2009-09-11) - 88(2)
-
legacy (2009-09-10) - 225
-
legacy (2009-06-15) - 287
-
memorandum-articles (2009-06-15) - MEM/ARTS
-
legacy (2009-06-12) - 288a
-
legacy (2009-06-02) - 288a
-
legacy (2009-06-02) - 287
-
certificate-change-of-name-company (2009-05-29) - CERTNM
-
legacy (2009-05-06) - 287