-
STREAM COMMS LIMITED - Carter House Chilton Business Centre, Chilton, Aylesbury, Bucks, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06847832
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Carter House Chilton Business Centre
- Chilton
- Aylesbury
- Bucks
- HP18 9LS Carter House Chilton Business Centre, Chilton, Aylesbury, Bucks, HP18 9LS UK
Management
- Geschäftsführung
- MACLURE, John Mark
- PARKER, Melanie Claire
- LLOYD, Laura Jayne
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.03.2009
- Alter der Firma 2009-03-16 15 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Mark Maclure
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-09
- Letzte Einreichung: 2021-03-26
-
STREAM COMMS LIMITED Firmenbeschreibung
- STREAM COMMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06847832. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.03.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Carter House Chilton Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern STREAM COMMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stream Comms Limited - Carter House Chilton Business Centre, Chilton, Aylesbury, Bucks, Grossbritannien
- 2009-03-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STREAM COMMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-21) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-26) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-18) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-26) - AAMD
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-20) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-12) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-04-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-09) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-29) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-05) - 88(2)
-
resolution (2009-03-23) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2009-03-16) - NEWINC
-
legacy (2009-03-17) - 288b