-
C T H HIRE CENTRES LIMITED - 149 Upper Weybourne Lane, Farnham, Surrey, GU9 9DD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06847222
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 149 Upper Weybourne Lane
- Farnham
- Surrey
- GU9 9DD
- United Kingdom 149 Upper Weybourne Lane, Farnham, Surrey, GU9 9DD, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- LUKAJ, Nusrer
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.03.2009
- Alter der Firma 2009-03-16 15 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Russell Hobbins
- Mr Gary John Harding
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-30
- Letzte Einreichung: 2021-03-16
-
C T H HIRE CENTRES LIMITED Firmenbeschreibung
- C T H HIRE CENTRES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06847222. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.03.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 29/02/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.03.2013.Die Firma kann schriftlich über 149 Upper Weybourne Lane erreicht werden.
Jetzt sichern C T H HIRE CENTRES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: C T H Hire Centres Limited - 149 Upper Weybourne Lane, Farnham, Surrey, GU9 9DD, Grossbritannien
- 2009-03-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu C T H HIRE CENTRES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-11-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-16) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-08-27) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-08-17) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-09-02) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-09-19) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-19) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-20) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-20) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-20) - PSC09
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-08) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-10-12) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-02-02) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-10) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-04-02) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-09-08) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-10-26) - AA
-
termination-director-company-with-name (2010-05-24) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-17) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2010-01-20) - TM01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-03-16) - NEWINC