-
LBTB LIMITED - Townshend House, Crown Road, Norwich, NR1 3DT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06831598
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Townshend House
- Crown Road
- Norwich
- NR1 3DT Townshend House, Crown Road, Norwich, NR1 3DT UK
Management
- Geschäftsführung
- BEEVERS, Colin Bartlett
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.02.2009
- Alter der Firma 2009-02-27 15 Jahre
- SIC/NACE
- 64205
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Colin Bartlett Beevers
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800I3FLXQIP42Q667
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-10
- Letzte Einreichung: 2020-02-27
-
LBTB LIMITED Firmenbeschreibung
- LBTB LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06831598. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.02.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64205" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Townshend House erreicht werden.
Jetzt sichern LBTB LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lbtb Limited - Townshend House, Crown Road, Norwich, NR1 3DT, Grossbritannien
- 2009-02-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LBTB LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-06-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-04-21) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-28) - CS01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-04-21) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-04-21) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-09) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-11-12) - AA
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2019-05-14) - SH02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-10) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-08) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-11-26) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-08-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-22) - AR01
-
capital-cancellation-shares (2015-11-26) - SH06
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-12-24) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-10-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-04) - AR01
-
resolution (2014-04-08) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-10-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-12-12) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-08-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-08-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-10-20) - MG01
-
legacy (2009-04-15) - 225
-
legacy (2009-04-09) - 88(2)
-
legacy (2009-04-09) - 123
-
resolution (2009-04-09) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2009-02-27) - NEWINC