-
P S EVENTS MANAGEMENT LTD - 22a Main Street, Garforth, Leeds, LS25 1AA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06826453
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 22a Main Street
- Garforth
- Leeds
- LS25 1AA 22a Main Street, Garforth, Leeds, LS25 1AA UK
Management
- Geschäftsführung
- AZIM, Mohammed
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.02.2009
- Gelöscht am:
- 2022-02-15
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mohammed Azim
- Mr Mohammed Azim
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-02-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-29
- Letzte Einreichung: 2020-03-18
-
P S EVENTS MANAGEMENT LTD Firmenbeschreibung
- P S EVENTS MANAGEMENT LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06826453. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.02.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.02.2012.Die Firma kann schriftlich über 22A Main Street erreicht werden.
Jetzt sichern P S EVENTS MANAGEMENT LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: P S Events Management Ltd - 22a Main Street, Garforth, Leeds, LS25 1AA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu P S EVENTS MANAGEMENT LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-11-15) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-06-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-01) - AD01
-
resolution (2020-04-21) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-04-21) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-06-19) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-18) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-29) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-03) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-24) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-27) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-17) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-22) - AA
-
termination-director-company-with-name (2011-12-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-12) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-21) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-03) - AR01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2011-01-24) - AAMD
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-02-23) - NEWINC
-
legacy (2009-06-09) - 225