-
NORFOLK TOOL & INDUSTRIAL SUPPLIES LIMITED - 12 High Street, Stanford-Le-Hope, SS17 0EY, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06824755
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 12 High Street
- Stanford-Le-Hope
- SS17 0EY
- England 12 High Street, Stanford-Le-Hope, SS17 0EY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LAMBERT, Simon David
- Prokuristen
- LAMBERT, Sarah
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.02.2009
- Alter der Firma 2009-02-19 15 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Simon David Lambert
- Simon David Lambert
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-27
- Letzte Einreichung: 2021-02-13
-
NORFOLK TOOL & INDUSTRIAL SUPPLIES LIMITED Firmenbeschreibung
- NORFOLK TOOL & INDUSTRIAL SUPPLIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06824755. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.02.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.02.2013.Die Firma kann schriftlich über 12 High Street erreicht werden.
Jetzt sichern NORFOLK TOOL & INDUSTRIAL SUPPLIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Norfolk Tool & Industrial Supplies Limited - 12 High Street, Stanford-Le-Hope, SS17 0EY, England, Grossbritannien
- 2009-02-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NORFOLK TOOL & INDUSTRIAL SUPPLIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-05-15) - DS01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-12-16) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-12-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-07-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-05) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-01-05) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-23) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-28) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-14) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-04-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-07-10) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-05) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-26) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-03-16) - MG01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-03-17) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-17) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-17) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2010-08-13) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-26) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-08-03) - 88(2)
-
legacy (2009-03-12) - 88(2)
-
legacy (2009-03-12) - 225
-
legacy (2009-03-02) - 288b
-
legacy (2009-03-02) - 288a
-
incorporation-company (2009-02-19) - NEWINC