-
C & C GREEN ENERGY LTD - Hamilton House 80 Stokes Croft, Bristol, Avon, BS1 3QY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06798638
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hamilton House 80 Stokes Croft
- Bristol
- Avon
- BS1 3QY Hamilton House 80 Stokes Croft, Bristol, Avon, BS1 3QY UK
Management
- Geschäftsführung
- CONNOLLY, Francis Joseph
- Prokuristen
- BAKER, Andrew Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.01.2009
- Gelöscht am:
- 2022-04-19
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mrs Mary Helen Connolly
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- ORGANIC POWER PROJECTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2020-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-17
- Letzte Einreichung: 2020-12-03
-
C & C GREEN ENERGY LTD Firmenbeschreibung
- C & C GREEN ENERGY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06798638. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 22.01.2009 registriert. C & C GREEN ENERGY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ORGANIC POWER PROJECTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Hamilton House 80 Stokes Croft erreicht werden.
Jetzt sichern C & C GREEN ENERGY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: C & C Green Energy Ltd - Hamilton House 80 Stokes Croft, Bristol, Avon, BS1 3QY, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu C & C GREEN ENERGY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
gazette-notice-compulsory (2022-01-04) - GAZ1
-
dissolution-application-strike-off-company (2022-01-25) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2022-02-01) - GAZ1(A)
-
gazette-dissolved-voluntary (2022-04-19) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-10-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-10-25) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-31) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-26) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-29) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-29) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-10-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-10-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-01) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-03) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-07-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-31) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2013-01-29) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-02-12) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-11) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-05-03) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-01-08) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-23) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-24) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-03-24) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
memorandum-articles (2009-06-23) - MEM/ARTS
-
certificate-change-of-name-company (2009-06-19) - CERTNM
-
legacy (2009-06-12) - 288a
-
incorporation-company (2009-01-22) - NEWINC