-
MOSAIC PRINT MANAGEMENT (YORK) LIMITED - Leigh House, 28-32 St Paul's Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06797603
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Leigh House
- 28-32 St Paul's Street
- Leeds
- West Yorkshire
- LS1 2JT Leigh House, 28-32 St Paul's Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 2JT UK
Management
- Geschäftsführung
- GILL, Anthony Stephen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.01.2009
- Alter der Firma 2009-01-21 15 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mosaic Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-04-30
- Letzte Einreichung: 2021-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-04
- Letzte Einreichung: 2021-01-21
-
MOSAIC PRINT MANAGEMENT (YORK) LIMITED Firmenbeschreibung
- MOSAIC PRINT MANAGEMENT (YORK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06797603. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.01.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Leigh House erreicht werden.
Jetzt sichern MOSAIC PRINT MANAGEMENT (YORK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mosaic Print Management (York) Limited - Leigh House, 28-32 St Paul's Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2009-01-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MOSAIC PRINT MANAGEMENT (YORK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-12-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-04-12) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-01-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-02-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-24) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-24) - PSC05
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-23) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-04-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-13) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-09-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-05-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-01) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2010-02-10) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-20) - CH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2010-05-18) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-04-29) - AA
-
resolution (2010-05-18) - RESOLUTIONS
-
statement-of-companys-objects (2010-05-18) - CC04
-
memorandum-articles (2010-05-28) - MEM/ARTS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-04-20) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-01-21) - NEWINC