-
ELLESMERE CONTRACTING LTD - Airport House, Suite 43 - 45, Purley Way, Croydon, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06793664
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Airport House
- Suite 43 - 45, Purley Way
- Croydon
- Surrey
- CR0 0XZ Airport House, Suite 43 - 45, Purley Way, Croydon, Surrey, CR0 0XZ UK
Management
- Geschäftsführung
- FARRINGTON, Daniel
- O'KEEFE, Linda Sharon
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.01.2009
- Alter der Firma 2009-01-16 15 Jahre
- SIC/NACE
- 43341
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Linda Sharon O'Keefe
- Mr Daniel Farrington
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- ALPINE HOLDINGS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-10-30
- Letzte Einreichung: 2023-01-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-30
- Letzte Einreichung: 2024-01-16
-
ELLESMERE CONTRACTING LTD Firmenbeschreibung
- ELLESMERE CONTRACTING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06793664. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.01.2009 registriert. ELLESMERE CONTRACTING LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ALPINE HOLDINGS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43341" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Airport House erreicht werden.
Jetzt sichern ELLESMERE CONTRACTING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ellesmere Contracting Ltd - Airport House, Suite 43 - 45, Purley Way, Croydon, Surrey, Grossbritannien
- 2009-01-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ELLESMERE CONTRACTING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-01-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
capital-allotment-shares (2023-01-25) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-01-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-10-30) - AA
-
resolution (2023-01-25) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-04-12) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-11) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2022-04-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-17) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-01-17) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-14) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-10-29) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-07) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-08-01) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-01) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-11) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-26) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-26) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2013-04-25) - CERTNM
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-03-28) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-21) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-09-08) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-10-05) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-17) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-17) - 288a
-
legacy (2009-09-14) - 288b
-
legacy (2009-03-23) - 287
-
incorporation-company (2009-01-16) - NEWINC