-
THE FLAG WIZARD LIMITED - 66 St Peters Avenue, Cleethorpes, Lincolnshire, DN35 8HP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06770719
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 66 St Peters Avenue
- Cleethorpes
- Lincolnshire
- DN35 8HP
- United Kingdom 66 St Peters Avenue, Cleethorpes, Lincolnshire, DN35 8HP, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BREWER, Jonathan Luke
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.12.2008
- Alter der Firma 2008-12-11 15 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Stuart Maclaren
- Affinity Partnerships Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-08
- Letzte Einreichung: 2020-12-25
-
THE FLAG WIZARD LIMITED Firmenbeschreibung
- THE FLAG WIZARD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06770719. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.12.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 66 St Peters Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern THE FLAG WIZARD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Flag Wizard Limited - 66 St Peters Avenue, Cleethorpes, Lincolnshire, DN35 8HP, Grossbritannien
- 2008-12-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE FLAG WIZARD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-08-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-13) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-13) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-13) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-02) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-24) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-09-24) - PSC05
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-15) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-10) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-12) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-04-29) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-28) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-03-21) - GAZ1
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-12-21) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-14) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-09-21) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-09-21) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-21) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-17) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-31) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-07-31) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-09-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-09-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-17) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-09-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-08-16) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-12-11) - NEWINC