-
PF FILM UK LIMITED - C/O GRANT THORNTON UK LLP, 30 Finsbury Square, London, EC2P 2YU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06764074
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O GRANT THORNTON UK LLP
- 30 Finsbury Square
- London
- EC2P 2YU C/O GRANT THORNTON UK LLP, 30 Finsbury Square, London, EC2P 2YU UK
Management
- Geschäftsführung
- BAGARIYA, Jateen Popatlal
- Prokuristen
- DERRINGTONS LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.12.2008
- Gelöscht am:
- 2021-05-02
- SIC/NACE
- 9999
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- 37 DEAN STREET LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2011-12-31
- Letzte Einreichung: 2009-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2010-12-02
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-12-16
- Letzte Einreichung:
-
PF FILM UK LIMITED Firmenbeschreibung
- PF FILM UK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06764074. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 02.12.2008 registriert. PF FILM UK LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen 37 DEAN STREET LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "9999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/12/2009 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 02.12.2010.Die Firma kann schriftlich über C/o Grant Thornton Uk Llp erreicht werden.
Jetzt sichern PF FILM UK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pf Film Uk Limited - C/O GRANT THORNTON UK LLP, 30 Finsbury Square, London, EC2P 2YU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PF FILM UK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-02-02) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-05-02) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-06-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-07-01) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-05-30) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-06-21) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-06-23) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-05-20) - 4.68
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2013-12-23) - LIQ MISC OC
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2013-12-23) - 4.40
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2013-05-25) - 4.68
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-12) - AD01
-
liquidation-miscellaneous (2013-04-11) - LIQ MISC
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2013-04-11) - 600
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2013-01-29) - 4.40
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2012-04-23) - 4.20
-
resolution (2012-04-23) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2012-04-23) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-04-05) - AD01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2012-02-29) - CH04
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-07-25) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2011-06-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-01-17) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2011-01-12) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-01-12) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-09) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2010-11-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-31) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-12-02) - NEWINC