-
RDF PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED - 22 Hayhill Ind. Est., Sileby Road Barrow-Upon-Soar, Loughborough, LE12 8LD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06755151
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 22 Hayhill Ind. Est.
- Sileby Road Barrow-Upon-Soar
- Loughborough
- LE12 8LD 22 Hayhill Ind. Est., Sileby Road Barrow-Upon-Soar, Loughborough, LE12 8LD UK
Management
- Geschäftsführung
- FOTHERGILL, David John
- FOTHERGILL, Robert Daniel
- WYATT, Sarah Anne
- Prokuristen
- FOTHERGILL, Robert Daniel
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.11.2008
- Alter der Firma 2008-11-21 15 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Robert Daniel Fothergill
- Mr David John Fothergill
- Mrs Sarah Anne Wyatt
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-12-29
- Letzte Einreichung: 2021-12-15
-
RDF PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- RDF PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06755151. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.11.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 22 Hayhill Ind. Est. erreicht werden.
Jetzt sichern RDF PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rdf Property Developments Limited - 22 Hayhill Ind. Est., Sileby Road Barrow-Upon-Soar, Loughborough, LE12 8LD, Grossbritannien
- 2008-11-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RDF PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-16) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-03-25) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-15) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-21) - CS01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2019-05-15) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-06) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-01) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-07) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-08) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-25) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-11-25) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-11-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-10-25) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-07-22) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-07-22) - CH03
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-07-13) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-02) - CH01
-
legacy (2010-07-08) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
capital-allotment-shares (2009-11-13) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-23) - CH01
-
legacy (2009-04-23) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-08) - 88(2)
-
incorporation-company (2008-11-21) - NEWINC
-
legacy (2008-11-27) - 225
-
legacy (2008-12-08) - 288a