-
BEAT CONTRACTING LIMITED - 120 St. Leonards Road, Northampton, Northamptonshire, NN4 8DW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06749440
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 120 St. Leonards Road
- Northampton
- Northamptonshire
- NN4 8DW 120 St. Leonards Road, Northampton, Northamptonshire, NN4 8DW UK
Management
- Geschäftsführung
- PASTON, Nigel Arthur
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.11.2008
- Alter der Firma 2008-11-14 15 Jahre
- SIC/NACE
- 43220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Nigel Arthur Paston
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2011-11-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-11-26
- Letzte Einreichung: 2018-11-12
-
BEAT CONTRACTING LIMITED Firmenbeschreibung
- BEAT CONTRACTING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06749440. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.11.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.11.2011.Die Firma kann schriftlich über 120 St. Leonards Road erreicht werden.
Jetzt sichern BEAT CONTRACTING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Beat Contracting Limited - 120 St. Leonards Road, Northampton, Northamptonshire, NN4 8DW, Grossbritannien
- 2008-11-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BEAT CONTRACTING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-11-12) - DISS16(SOAS)
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-01-11) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-03) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-03) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-03) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-03) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-10-03) - TM02
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-10-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-04-06) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-03) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2013-03-12) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-10-08) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-10-08) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-04-07) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date (2012-04-04) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2012-03-13) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-16) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-11-16) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-18) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-19) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-19) - 225
-
incorporation-company (2008-11-14) - NEWINC