-
COMPLETE BUILDING CONTROL LTD - 36 George Road Edgbaston, Birmingham, West Midlands, B15 1PL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06738119
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 36 George Road Edgbaston
- Birmingham
- West Midlands
- B15 1PL 36 George Road Edgbaston, Birmingham, West Midlands, B15 1PL UK
Management
- Geschäftsführung
- BASSI, Bhinder Singh
- BRADSHAW, Robert Frederick
- GAY, Daniel
- HARRIES, Andrew David
- HOGARTH, Peter Norman
- PARKER, Clive Alan
- SINGH, Melap
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.10.2008
- Alter der Firma 2008-10-31 15 Jahre
- SIC/NACE
- 71129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Melap Singh
- Mr Melap Singh
- Mr Clive Alan Parker
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-03
- Letzte Einreichung: 2020-10-20
-
COMPLETE BUILDING CONTROL LTD Firmenbeschreibung
- COMPLETE BUILDING CONTROL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06738119. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.10.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71129" registriert. Das Unternehmen hat 7 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 36 George Road Edgbaston erreicht werden.
Jetzt sichern COMPLETE BUILDING CONTROL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Complete Building Control Ltd - 36 George Road Edgbaston, Birmingham, West Midlands, B15 1PL, Grossbritannien
- 2008-10-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COMPLETE BUILDING CONTROL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-16) - MR01
-
memorandum-articles (2020-10-27) - MA
-
resolution (2020-10-27) - RESOLUTIONS
-
second-filing-capital-allotment-shares (2020-10-24) - RP04SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-23) - AA
-
statement-of-companys-objects (2020-10-27) - CC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-10-29) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-25) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-05) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-24) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-07) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-12) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-03) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-07-31) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-18) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-01) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-09-21) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-18) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2013-10-31) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-06-19) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-08) - AR01
-
capital-allotment-shares (2010-12-08) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-29) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2010-07-21) - TM02
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-25) - AR01
-
legacy (2009-06-18) - 288a
-
legacy (2009-05-07) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-11) - 288c
-
incorporation-company (2008-10-31) - NEWINC