-
PTS DEMOLITION AND DISMANTLING LIMITED - Barrier Works, Hackworth Industrial Park, Shildon, Co. Durham, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06715549
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Barrier Works
- Hackworth Industrial Park
- Shildon
- Co. Durham
- DL4 1HF
- England Barrier Works, Hackworth Industrial Park, Shildon, Co. Durham, DL4 1HF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GAUJA, David Taisto
- Prokuristen
- HUNTROD, Dawn
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.10.2008
- Gelöscht am:
- 2023-01-19
- SIC/NACE
- 38320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Taisto Gauja
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- POLYMER TECHNICAL SOLUTIONS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-10-20
- Letzte Einreichung: 2019-10-06
-
PTS DEMOLITION AND DISMANTLING LIMITED Firmenbeschreibung
- PTS DEMOLITION AND DISMANTLING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06715549. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.10.2008 registriert. PTS DEMOLITION AND DISMANTLING LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen POLYMER TECHNICAL SOLUTIONS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "38320" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Barrier Works erreicht werden.
Jetzt sichern PTS DEMOLITION AND DISMANTLING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pts Demolition And Dismantling Limited - Barrier Works, Hackworth Industrial Park, Shildon, Co. Durham, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PTS DEMOLITION AND DISMANTLING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2019-01-16) - CVA3
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-19) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2019-12-06) - CVA3
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-24) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-10-11) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-28) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-28) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-31) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-11) - CS01
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2017-11-15) - CVA1
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2017-10-10) - AD02
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-06) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-16) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-10-16) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-06) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-09-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-16) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2012-07-03) - CERTNM
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-03-29) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-14) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-03-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-05-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-20) - AR01
-
move-registers-to-sail-company (2009-10-20) - AD03
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-19) - CH01
-
change-sail-address-company (2009-10-19) - AD02
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-15) - 225
-
legacy (2008-10-15) - 88(2)
-
legacy (2008-10-15) - 288a
-
incorporation-company (2008-10-06) - NEWINC