-
CELTIC SPRINGS RETAIL LIMITED - Sherbourne House Rear Of 378 Cyncoed Road, Cyncoed, Cardiff, CF23 8SA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06704667
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Sherbourne House Rear Of 378 Cyncoed Road
- Cyncoed
- Cardiff
- CF23 8SA Sherbourne House Rear Of 378 Cyncoed Road, Cyncoed, Cardiff, CF23 8SA UK
Management
- Geschäftsführung
- HERBERT, David Robert James
- Prokuristen
- HERBERT, Samantha Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.09.2008
- Gelöscht am:
- 2023-01-03
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Robert James Herbert
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- BEALAW (918) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-07
- Letzte Einreichung: 2020-09-23
-
CELTIC SPRINGS RETAIL LIMITED Firmenbeschreibung
- CELTIC SPRINGS RETAIL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06704667. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.09.2008 registriert. CELTIC SPRINGS RETAIL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BEALAW (918) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Sherbourne House Rear Of 378 Cyncoed Road erreicht werden.
Jetzt sichern CELTIC SPRINGS RETAIL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Celtic Springs Retail Limited - Sherbourne House Rear Of 378 Cyncoed Road, Cyncoed, Cardiff, CF23 8SA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CELTIC SPRINGS RETAIL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-02-23) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-02-26) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-10-23) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-10-23) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-10-23) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-06-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-23) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-02-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-04-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-06-09) - AA
-
termination-director-company-with-name (2010-01-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-01-27) - AP01
-
appoint-corporate-director-company-with-name (2010-01-27) - AP02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-06-15) - 288b
-
legacy (2009-06-15) - 288a
-
certificate-change-of-name-company (2009-06-11) - CERTNM
-
legacy (2009-06-15) - 287
-
legacy (2009-08-05) - 395
-
resolution (2009-08-07) - RESOLUTIONS
-
legacy (2009-08-17) - 88(2)
-
legacy (2009-10-24) - MG01
-
legacy (2009-07-01) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-08) - 652C
-
legacy (2008-09-30) - 652a
-
incorporation-company (2008-09-23) - NEWINC