-
MIRAGE HR LTD - Mackenzie Goldberg Johnson Limited Scope House, Weston Road, Crewe, CW1 6DD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06703733
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Mackenzie Goldberg Johnson Limited Scope House
- Weston Road
- Crewe
- CW1 6DD Mackenzie Goldberg Johnson Limited Scope House, Weston Road, Crewe, CW1 6DD UK
Management
- Geschäftsführung
- MOUNTFORD, Nicholas John
- MOUNTFORD, Susan
- Prokuristen
- MOUNTFORD, Susan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.09.2008
- Alter der Firma 2008-09-22 15 Jahre
- SIC/NACE
- 78200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nicholas John Mountford
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- MIRAGE DESIGN & BUILD LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2020-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-10-20
- Letzte Einreichung: 2019-10-06
-
MIRAGE HR LTD Firmenbeschreibung
- MIRAGE HR LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06703733. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.09.2008 registriert. MIRAGE HR LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MIRAGE DESIGN & BUILD LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Mackenzie Goldberg Johnson Limited Scope House erreicht werden.
Jetzt sichern MIRAGE HR LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mirage Hr Ltd - Mackenzie Goldberg Johnson Limited Scope House, Weston Road, Crewe, CW1 6DD, Grossbritannien
- 2008-09-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MIRAGE HR LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-19) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-03-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-08-02) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-05-22) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-21) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-19) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-19) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-06-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-06-30) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-06) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-06) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-medium (2016-07-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-11) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-05) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-20) - AD01
-
capital-allotment-shares (2012-10-25) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2012-07-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-11) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-17) - AA
-
legacy (2011-11-25) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-02) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-11-02) - AD01
-
capital-allotment-shares (2010-10-27) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-21) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-06-17) - AA
-
legacy (2010-01-05) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-13) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2009-09-12) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-09-22) - NEWINC