-
BETTER LIVING HOUSING LIMITED - 21-23 Croydon Road, Caterham, Surrey, CR3 6PA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06662489
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 21-23 Croydon Road
- Caterham
- Surrey
- CR3 6PA
- England 21-23 Croydon Road, Caterham, Surrey, CR3 6PA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- PATEL, Nimesh Dilip
- Prokuristen
- PATEL, Nimesh Dilip
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.08.2008
- Alter der Firma 2008-08-01 15 Jahre
- SIC/NACE
- 87300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Mohammed Menair
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-15
- Letzte Einreichung: 2020-08-01
-
BETTER LIVING HOUSING LIMITED Firmenbeschreibung
- BETTER LIVING HOUSING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06662489. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.08.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87300" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 21-23 Croydon Road erreicht werden.
Jetzt sichern BETTER LIVING HOUSING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Better Living Housing Limited - 21-23 Croydon Road, Caterham, Surrey, CR3 6PA, Grossbritannien
- 2008-08-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BETTER LIVING HOUSING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2021-06-29) - RP04CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-06-07) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-06-07) - PSC07
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-11) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-08) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-05) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-07) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-12) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-07) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-17) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-06) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-21) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-05-28) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-01-14) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2014-01-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-11-27) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2013-11-26) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-31) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2012-09-10) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-10-06) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-16) - AR01
-
capital-allotment-shares (2010-07-22) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-22) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-01) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-08-01) - NEWINC