-
CM SUBCO 1 LIMITED - The Chancery, 58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06660733
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Chancery
- 58 Spring Gardens
- Manchester
- M2 1EW The Chancery, 58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW UK
Management
- Geschäftsführung
- AUSTIN, Philip Lang
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.07.2008
- Gelöscht am:
- 2021-11-21
- SIC/NACE
- 7487
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- COMMUNITY COMMUNICATION NETWORKS (EUROPE) LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2011-09-30
- Letzte Einreichung: 2009-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2010-07-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-08-13
- Letzte Einreichung:
-
CM SUBCO 1 LIMITED Firmenbeschreibung
- CM SUBCO 1 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06660733. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 30.07.2008 registriert. CM SUBCO 1 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen COMMUNITY COMMUNICATION NETWORKS (EUROPE) LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "7487" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2009 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.07.2010.Die Firma kann schriftlich über The Chancery erreicht werden.
Jetzt sichern CM SUBCO 1 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cm Subco 1 Limited - The Chancery, 58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CM SUBCO 1 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-11-21) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-21) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-08-21) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-08-21) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-01) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-01) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-10-05) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-08-18) - 600
-
resolution (2018-08-18) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2017-07-19) - 2.12B
-
restoration-order-of-court (2017-07-19) - AC92
keyboard_arrow_right 2012
-
gazette-dissolved-liquidation (2012-07-17) - GAZ2
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2012-05-09) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-move-to-dissolution (2012-04-17) - 2.35B
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-secretary-company-with-name (2011-04-12) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-19) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2011-04-27) - 2.12B
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2011-06-09) - 2.16B
-
change-of-name-notice (2011-06-13) - CONNOT
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2011-11-23) - 2.24B
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2011-06-23) - F2.18
-
termination-director-company-with-name (2011-01-17) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2011-06-13) - CERTNM
-
liquidation-in-administration-proposals (2011-06-20) - 2.17B
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-12-03) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-27) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-12-03) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-10-01) - AA
-
termination-director-company-with-name (2010-05-06) - TM01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-08-27) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-29) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-09-01) - AA
-
legacy (2009-08-26) - 363a
-
legacy (2009-05-19) - 395
-
legacy (2009-05-07) - 288a
-
legacy (2009-04-27) - 288b
-
legacy (2009-04-27) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-08) - 288a
-
legacy (2008-08-08) - 288b
-
memorandum-articles (2008-08-13) - MEM/ARTS
-
legacy (2008-08-13) - 287
-
legacy (2008-10-01) - 225
-
statement-of-affairs (2008-08-21) - SA
-
legacy (2008-08-28) - 288a
-
incorporation-company (2008-07-30) - NEWINC
-
legacy (2008-12-24) - 395
-
legacy (2008-08-21) - 88(2)
-
certificate-change-of-name-company (2008-08-07) - CERTNM