-
WOODCOTE MECHANICAL SERVICES LIMITED - Airport House, Suite 43 - 45, Croydon, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06645923
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Airport House
- Suite 43 - 45
- Croydon
- Surrey
- CR0 0XZ Airport House, Suite 43 - 45, Croydon, Surrey, CR0 0XZ UK
Management
- Geschäftsführung
- MATHIE, Dean Garry
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.07.2008
- Alter der Firma 2008-07-14 15 Jahre
- SIC/NACE
- 43220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Dean Garry Mathie
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-10-28
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-08-25
- Letzte Einreichung: 2022-08-11
-
WOODCOTE MECHANICAL SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- WOODCOTE MECHANICAL SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06645923. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.07.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Airport House erreicht werden.
Jetzt sichern WOODCOTE MECHANICAL SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Woodcote Mechanical Services Limited - Airport House, Suite 43 - 45, Croydon, Surrey, Grossbritannien
- 2008-07-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WOODCOTE MECHANICAL SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2024-01-06) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-12-26) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2022
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-09-26) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-09-26) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2022-07-28) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-09-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-12-02) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-01) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-02) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-31) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2020-12-01) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-12-18) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-11) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-04-10) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-28) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-21) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-29) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-08-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-19) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-28) - 363a
-
legacy (2009-03-13) - 288a
-
legacy (2009-03-12) - 288b
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-07-14) - NEWINC