-
CHEM SCAFFOLDING LIMITED - Horley Green House Horley Green Road, Claremount, Halifax, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06635065
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Horley Green House Horley Green Road
- Claremount
- Halifax
- West Yorkshire
- HX3 6AS Horley Green House Horley Green Road, Claremount, Halifax, West Yorkshire, HX3 6AS UK
Management
- Geschäftsführung
- BRENNAN, Joseph
- BRENNAN, Lesley
- Prokuristen
- BRENNAN, Joseph
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.07.2008
- Alter der Firma 2008-07-01 15 Jahre
- SIC/NACE
- 43991
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Lesley Brennan
- Mr Joseph Brennan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CHEM END LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-15
- Letzte Einreichung: 2020-07-01
-
CHEM SCAFFOLDING LIMITED Firmenbeschreibung
- CHEM SCAFFOLDING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06635065. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.07.2008 registriert. CHEM SCAFFOLDING LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CHEM END LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43991" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Horley Green House Horley Green Road erreicht werden.
Jetzt sichern CHEM SCAFFOLDING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Chem Scaffolding Limited - Horley Green House Horley Green Road, Claremount, Halifax, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2008-07-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHEM SCAFFOLDING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-28) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-16) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-07-03) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-13) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-14) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-08-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-20) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-07) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-15) - 363a
-
legacy (2009-07-15) - 353
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
resolution (2008-07-18) - RESOLUTIONS
-
legacy (2008-07-17) - 288b
-
legacy (2008-07-16) - 288a
-
legacy (2008-07-16) - 287
-
legacy (2008-07-16) - 88(2)
-
certificate-change-of-name-company (2008-07-03) - CERTNM
-
incorporation-company (2008-07-01) - NEWINC